
Bon Raclos, (#66173)
 Abt 1626 - 1671  (45 years)
 Abt 1626 - 1671  (45 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Bon Raclos, (#66173) [1]  b. Abt 1 Oct 1626 d. 11 Nov 1671
 Marie Viennot, (#66174)  b. Abt 1630 d. 11 Nov 1671 Marie Viennot, (#66174)  b. Abt 1630 d. 11 Nov 1671
 - 2  Françoise Raclos, (Fille du Roi)(#24482) [1.1]    b. Abt 20 Oct 1651 d. Abt 25 Nov 1723 b. Abt 20 Oct 1651 d. Abt 25 Nov 1723 Michel David, (#24363)  b. Abt 9 Apr 1650 d. 10 Mar 1692 Michel David, (#24363)  b. Abt 9 Apr 1650 d. 10 Mar 1692
 - 3  René David, (#24483) [1.1.1]    b. Abt 27 Apr 1676 d. 5 Apr 1723 b. Abt 27 Apr 1676 d. 5 Apr 1723 Marie Josèphe Dragon dit Guay, (#24527)  b. Abt 1696 d. Abt 29 Mar 1775 Marie Josèphe Dragon dit Guay, (#24527)  b. Abt 1696 d. Abt 29 Mar 1775
 - 4  Joseph David, (#30862) [1.1.1.1]    b. 3 Dec 1719 d. 13 May 1793 b. 3 Dec 1719 d. 13 May 1793 Marguerite Blain Marguerite Blain
 - 5  Marie Françoise David dit Boucher, (#151266)(√) [1.1.1.1.1]    b. 15 Feb 1741 d. Abt 10 May 1760 b. 15 Feb 1741 d. Abt 10 May 1760 Jean Baptiste Ménard dit Bellerose, (#151265)  b. 22 Apr 1735 d. 27 Jan 1785 Jean Baptiste Ménard dit Bellerose, (#151265)  b. 22 Apr 1735 d. 27 Jan 1785
 - 6  Marie Ménard dit Bellerose, (#219420) [1.1.1.1.1.1]    b. 27 Feb 1756 d. 26 Mar 1793 b. 27 Feb 1756 d. 26 Mar 1793 Antoine Dame, (#139478)  b. 5 May 1749 d. 18 Mar 1829 Antoine Dame, (#139478)  b. 5 May 1749 d. 18 Mar 1829
 - 7  Laurent Dame, (#591647) [1.1.1.1.1.1.1]    b. 8 Jun 1783 b. 8 Jun 1783 Marie Louise Chartier, (#591648)  b. 14 Aug 1788 Marie Louise Chartier, (#591648)  b. 14 Aug 1788
 - 8  Domitilde Dame, (C29) [1.1.1.1.1.1.1.1]    b. 27 Jul 1828 d. Aft 10 Jun 1880 b. 27 Jul 1828 d. Aft 10 Jun 1880 Joseph St-André, (#2249352)  b. 15 Dec 1810 d. 27 Jul 1882 Joseph St-André, (#2249352)  b. 15 Dec 1810 d. 27 Jul 1882
 - 9  Cylinda St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.1]    b. Abt 1848 b. Abt 1848
- 9  Joseph Colett St. Andrew, (C14) [1.1.1.1.1.1.1.1.2]    b. Abt 1850 b. Abt 1850 Mary Belleville, (C15)  b. Abt 1855 Mary Belleville, (C15)  b. Abt 1855
 - 10  Fred St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]    b. Abt 1881 b. Abt 1881- +  mary ann Baker  b. Abt 1883  
 
- +  mary ann Baker  b. Abt 1883  
- 10  Elizabeth St. Andrew, (C7) [1.1.1.1.1.1.1.1.2.2]    b. 21 Mar 1882 d. 13 Nov 1958 b. 21 Mar 1882 d. 13 Nov 1958 Wallace Russell Cook, (C6)  b. 27 Jul 1882 d. 5 Jan 1968 Wallace Russell Cook, (C6)  b. 27 Jul 1882 d. 5 Jan 1968
 - 11  Raymond Cook [1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1]    b. 24 Jan 1906 d. 12 Jun 1977 b. 24 Jan 1906 d. 12 Jun 1977
- 11  Hazel Cook [1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2]    b. 28 Mar 1907 d. 10 Oct 1961 b. 28 Mar 1907 d. 10 Oct 1961
- 11  Exzina C Cook, (C3) [1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3]    b. 27 Nov 1909 d. 9 Jun 1941 b. 27 Nov 1909 d. 9 Jun 1941 Lawrence George Patrie, (C2)  b. 29 Aug 1904 d. 18 Sep 1987 Lawrence George Patrie, (C2)  b. 29 Aug 1904 d. 18 Sep 1987
 - 12  Lawrence Raymond Patrie [1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.1]    b. 15 Nov 1928 d. 1 Feb 1929 b. 15 Nov 1928 d. 1 Feb 1929
- 12  Janet Emma Patrie, (C1) [1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.2]    b. 28 Aug 1930 d. 31 Dec 2020
[ =>] b. 28 Aug 1930 d. 31 Dec 2020
[ =>]
- 12  Joyce Evelyn Patrie [1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.3]    [ =>] [ =>]
- 12  James George Patrie [1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.4]    [ =>] [ =>]
 
- 12  Lawrence Raymond Patrie [1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.1]   
 
- 11  Evelyn May Cook [1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4]    b. 6 Jul 1911 d. 1 Jul 2005 b. 6 Jul 1911 d. 1 Jul 2005
- 11  George W Cook [1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5]    b. 28 Apr 1916 d. 6 Apr 2002 b. 28 Apr 1916 d. 6 Apr 2002
 
- 11  Raymond Cook [1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1]   
 
- 10  Eli St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.2.3]    b. Abt 1888 b. Abt 1888
- 10  Joseph St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.2.4]    b. Abt 1889 b. Abt 1889
- 10  George St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.2.5]    b. 4 Sep 1892 d. 18 Sep 1964 b. 4 Sep 1892 d. 18 Sep 1964 Exina Baker  b. 7 Apr 1881 d. 29 Apr 1964 Exina Baker  b. 7 Apr 1881 d. 29 Apr 1964
 - 11  Madeline St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.1]    b. 5 Mar 1923 d. 19 Apr 1997 b. 5 Mar 1923 d. 19 Apr 1997 Andrus Roy Laventure  b. 8 Dec 1920 d. 24 Feb 1993 Andrus Roy Laventure  b. 8 Dec 1920 d. 24 Feb 1993
 - 12  Andrus Laventure, Jr. [1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.1.1]     
- 12  James Laventure [1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.1.2]     
- 12  Richard Laventure [1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.1.3]     
 
- 12  Andrus Laventure, Jr. [1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.1.1]   
 
 
- 11  Madeline St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.1]   
 
- 10  Lewis St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.2.6]    b. Abt 1893 b. Abt 1893
- 10  Camile St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.2.7]    b. Abt 1896 b. Abt 1896
- 10  Carneau St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.2.8]    b. Abt 1897 b. Abt 1897
 
- 10  Fred St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]   
 
- 9  Earnest St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.3]    b. Abt 1852 b. Abt 1852
- 9  Gladys St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.4]    b. Abt 1855 b. Abt 1855
- 9  Israel St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.5]    b. Abt 1856 b. Abt 1856
- 9  Adolphus St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.6]    b. Abt 1858 b. Abt 1858
- 9  Homer St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.7]    b. Abt 1860 b. Abt 1860
- 9  Arthur St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.8]    b. Abt 1862 b. Abt 1862
- 9  Delia St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.9]    b. Abt 1864 b. Abt 1864
- 9  Samuel St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.10]    b. Abt 1864 b. Abt 1864
- 9  Cordelia St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.11]    b. Abt 1867 b. Abt 1867
 
- 9  Cylinda St. Andrew [1.1.1.1.1.1.1.1.1]   
 
 
- 8  Domitilde Dame, (C29) [1.1.1.1.1.1.1.1]   
 
 
- 7  Laurent Dame, (#591647) [1.1.1.1.1.1.1]   
 
 
- 6  Marie Ménard dit Bellerose, (#219420) [1.1.1.1.1.1]   
 
 
- 5  Marie Françoise David dit Boucher, (#151266)(√) [1.1.1.1.1]   
 
- 4  Catherine David dit Lacourse, (#133991) [1.1.1.2]    b. 3 Jul 1722 d. 8 May 1786 b. 3 Jul 1722 d. 8 May 1786 Boucher Boucher
 - 5  Marie Françoise David dit Boucher, (#151266)(√) [1.1.1.2.1]    b. 15 Feb 1741 d. Abt 10 May 1760 b. 15 Feb 1741 d. Abt 10 May 1760 Jean Baptiste Ménard dit Bellerose, (#151265)  b. 22 Apr 1735 d. 27 Jan 1785 Jean Baptiste Ménard dit Bellerose, (#151265)  b. 22 Apr 1735 d. 27 Jan 1785
 - 6  Marie Ménard dit Bellerose, (#219420) [1.1.1.2.1.1]    b. 27 Feb 1756 d. 26 Mar 1793 b. 27 Feb 1756 d. 26 Mar 1793 Antoine Dame, (#139478)  b. 5 May 1749 d. 18 Mar 1829 Antoine Dame, (#139478)  b. 5 May 1749 d. 18 Mar 1829
 - 7  Laurent Dame, (#591647) [1.1.1.2.1.1.1]    b. 8 Jun 1783 b. 8 Jun 1783 Marie Louise Chartier, (#591648)  b. 14 Aug 1788 Marie Louise Chartier, (#591648)  b. 14 Aug 1788
 - 8  Domitilde Dame, (C29) [1.1.1.2.1.1.1.1]    b. 27 Jul 1828 d. Aft 10 Jun 1880 b. 27 Jul 1828 d. Aft 10 Jun 1880 Joseph St-André, (#2249352)  b. 15 Dec 1810 d. 27 Jul 1882 Joseph St-André, (#2249352)  b. 15 Dec 1810 d. 27 Jul 1882
 - 9  Cylinda St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.1]    b. Abt 1848 b. Abt 1848
- 9  Joseph Colett St. Andrew, (C14) [1.1.1.2.1.1.1.1.2]    b. Abt 1850 b. Abt 1850 Mary Belleville, (C15)  b. Abt 1855 Mary Belleville, (C15)  b. Abt 1855
 - 10  Fred St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.2.1]    b. Abt 1881 b. Abt 1881- +  mary ann Baker  b. Abt 1883  
 
- +  mary ann Baker  b. Abt 1883  
- 10  Elizabeth St. Andrew, (C7) [1.1.1.2.1.1.1.1.2.2]    b. 21 Mar 1882 d. 13 Nov 1958 b. 21 Mar 1882 d. 13 Nov 1958 Wallace Russell Cook, (C6)  b. 27 Jul 1882 d. 5 Jan 1968 Wallace Russell Cook, (C6)  b. 27 Jul 1882 d. 5 Jan 1968
 - 11  Raymond Cook [1.1.1.2.1.1.1.1.2.2.1]    b. 24 Jan 1906 d. 12 Jun 1977 b. 24 Jan 1906 d. 12 Jun 1977
- 11  Hazel Cook [1.1.1.2.1.1.1.1.2.2.2]    b. 28 Mar 1907 d. 10 Oct 1961 b. 28 Mar 1907 d. 10 Oct 1961
- 11  Exzina C Cook, (C3) [1.1.1.2.1.1.1.1.2.2.3]    b. 27 Nov 1909 d. 9 Jun 1941 b. 27 Nov 1909 d. 9 Jun 1941 Lawrence George Patrie, (C2)  b. 29 Aug 1904 d. 18 Sep 1987 Lawrence George Patrie, (C2)  b. 29 Aug 1904 d. 18 Sep 1987
 - 12  Lawrence Raymond Patrie [1.1.1.2.1.1.1.1.2.2.3.1]    b. 15 Nov 1928 d. 1 Feb 1929 b. 15 Nov 1928 d. 1 Feb 1929
- 12  Janet Emma Patrie, (C1) [1.1.1.2.1.1.1.1.2.2.3.2]    b. 28 Aug 1930 d. 31 Dec 2020
[ =>] b. 28 Aug 1930 d. 31 Dec 2020
[ =>]
- 12  Joyce Evelyn Patrie [1.1.1.2.1.1.1.1.2.2.3.3]    [ =>] [ =>]
- 12  James George Patrie [1.1.1.2.1.1.1.1.2.2.3.4]    [ =>] [ =>]
 
- 12  Lawrence Raymond Patrie [1.1.1.2.1.1.1.1.2.2.3.1]   
 
- 11  Evelyn May Cook [1.1.1.2.1.1.1.1.2.2.4]    b. 6 Jul 1911 d. 1 Jul 2005 b. 6 Jul 1911 d. 1 Jul 2005
- 11  George W Cook [1.1.1.2.1.1.1.1.2.2.5]    b. 28 Apr 1916 d. 6 Apr 2002 b. 28 Apr 1916 d. 6 Apr 2002
 
- 11  Raymond Cook [1.1.1.2.1.1.1.1.2.2.1]   
 
- 10  Eli St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.2.3]    b. Abt 1888 b. Abt 1888
- 10  Joseph St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.2.4]    b. Abt 1889 b. Abt 1889
- 10  George St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.2.5]    b. 4 Sep 1892 d. 18 Sep 1964 b. 4 Sep 1892 d. 18 Sep 1964 Exina Baker  b. 7 Apr 1881 d. 29 Apr 1964 Exina Baker  b. 7 Apr 1881 d. 29 Apr 1964
 - 11  Madeline St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.2.5.1]    b. 5 Mar 1923 d. 19 Apr 1997 b. 5 Mar 1923 d. 19 Apr 1997 Andrus Roy Laventure  b. 8 Dec 1920 d. 24 Feb 1993 Andrus Roy Laventure  b. 8 Dec 1920 d. 24 Feb 1993
 - 12  Andrus Laventure, Jr. [1.1.1.2.1.1.1.1.2.5.1.1]     
- 12  James Laventure [1.1.1.2.1.1.1.1.2.5.1.2]     
- 12  Richard Laventure [1.1.1.2.1.1.1.1.2.5.1.3]     
 
- 12  Andrus Laventure, Jr. [1.1.1.2.1.1.1.1.2.5.1.1]   
 
 
- 11  Madeline St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.2.5.1]   
 
- 10  Lewis St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.2.6]    b. Abt 1893 b. Abt 1893
- 10  Camile St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.2.7]    b. Abt 1896 b. Abt 1896
- 10  Carneau St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.2.8]    b. Abt 1897 b. Abt 1897
 
- 10  Fred St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.2.1]   
 
- 9  Earnest St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.3]    b. Abt 1852 b. Abt 1852
- 9  Gladys St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.4]    b. Abt 1855 b. Abt 1855
- 9  Israel St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.5]    b. Abt 1856 b. Abt 1856
- 9  Adolphus St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.6]    b. Abt 1858 b. Abt 1858
- 9  Homer St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.7]    b. Abt 1860 b. Abt 1860
- 9  Arthur St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.8]    b. Abt 1862 b. Abt 1862
- 9  Delia St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.9]    b. Abt 1864 b. Abt 1864
- 9  Samuel St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.10]    b. Abt 1864 b. Abt 1864
- 9  Cordelia St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.11]    b. Abt 1867 b. Abt 1867
 
- 9  Cylinda St. Andrew [1.1.1.2.1.1.1.1.1]   
 
 
- 8  Domitilde Dame, (C29) [1.1.1.2.1.1.1.1]   
 
 
- 7  Laurent Dame, (#591647) [1.1.1.2.1.1.1]   
 
 
- 6  Marie Ménard dit Bellerose, (#219420) [1.1.1.2.1.1]   
 
 
- 5  Marie Françoise David dit Boucher, (#151266)(√) [1.1.1.2.1]   
- +  Louis Emery dit Beauvais    
 
 
- 4  Joseph David, (#30862) [1.1.1.1]   
 
 
- 3  René David, (#24483) [1.1.1]   
 
- 2  Madeleine Raclos, (Fille du Roi)(S)(#62504) [1.2]    b. Abt 1655 d. Abt 8 Jul 1724 b. Abt 1655 d. Abt 8 Jul 1724 Nicolas Perrault, (From France)(#61866)  b. Abt 1643 d. 12 Aug 1717 Nicolas Perrault, (From France)(#61866)  b. Abt 1643 d. 12 Aug 1717
 - 3  Pierre Perrault, (#62508) [1.2.1]    b. Abt 1686 d. 7 Jun 1725 b. Abt 1686 d. 7 Jun 1725 Marie Champoux, (#14064)  b. Abt 20 Oct 1690 d. Abt 25 Apr 1715 Marie Champoux, (#14064)  b. Abt 20 Oct 1690 d. Abt 25 Apr 1715
 - 4  Marie Madeleine Perrault, (#86357) [1.2.1.1]    b. Abt 12 Nov 1712 d. 3 Mar 1796 b. Abt 12 Nov 1712 d. 3 Mar 1796 Noël Morin, (#86356)  b. 7 Apr 1708 d. 20 Mar 1758 Noël Morin, (#86356)  b. 7 Apr 1708 d. 20 Mar 1758
 - 5  Marie Angélique Morin, (#124785) [1.2.1.1.1]    b. 1 Nov 1745 d. 8 Nov 1832 b. 1 Nov 1745 d. 8 Nov 1832 Pierre Marie Laporte dit St-Georges, (#100211)  b. 6 Apr 1738 d. Bef 16 Jan 1781 Pierre Marie Laporte dit St-Georges, (#100211)  b. 6 Apr 1738 d. Bef 16 Jan 1781
 - 6  Marquerite Angélique Laporte dit St-Georges, (#86147) [1.2.1.1.1.1]    b. 9 Sep 1767 d. 3 May 1825 b. 9 Sep 1767 d. 3 May 1825 Michel Dufour dit Latour, (#225033)  b. 14 Nov 1768 d. 8 Mar 1840 Michel Dufour dit Latour, (#225033)  b. 14 Nov 1768 d. 8 Mar 1840
 - 7  Marie Émilie Dufour dit Latour, (#671527) [1.2.1.1.1.1.1]    b. 18 Jun 1803 b. 18 Jun 1803 Pierre Berthiaume, (#671526)  b. 8 Oct 1798 Pierre Berthiaume, (#671526)  b. 8 Oct 1798
 - 8  Pierre Berthiaume [1.2.1.1.1.1.1.1]    b. 5 Jan 1825 d. 9 Apr 1894 b. 5 Jan 1825 d. 9 Apr 1894
- 8  Olive Berthiaume, (#2703793) [1.2.1.1.1.1.1.2]    b. 28 Oct 1826 d. Apr 1870 b. 28 Oct 1826 d. Apr 1870 Laurent Phaneuf, (#952490)  b. 16 Jan 1832 d. 16 Oct 1914 Laurent Phaneuf, (#952490)  b. 16 Jan 1832 d. 16 Oct 1914
 - 9  Joseph Phaneuf, (A10) [1.2.1.1.1.1.1.2.1]    b. 12 Dec 1853 d. 19 Apr 1902 b. 12 Dec 1853 d. 19 Apr 1902 Olive Lamarque, (A11)  b. 26 Dec 1854 d. 2 Aug 1923 Olive Lamarque, (A11)  b. 26 Dec 1854 d. 2 Aug 1923
 - 10  Marie J Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1]    b. 14 Aug 1875 b. 14 Aug 1875 Joseph McCormick  b. Abt 1870 Joseph McCormick  b. Abt 1870
 - 11  Ida May McCormick [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1]    b. 4 Sep 1895 d. 16 Oct 1989 b. 4 Sep 1895 d. 16 Oct 1989
- 11  James Joseph McCormick [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.2]    b. 12 May 1897 d. 15 Nov 1990 b. 12 May 1897 d. 15 Nov 1990
 
- 11  Ida May McCormick [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1]   
 Orrin J Young  b. Abt 1864 Orrin J Young  b. Abt 1864
 - 11  Orrin E Young [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.3]    b. Abt 1905 d. deceased b. Abt 1905 d. deceased
- 11  Jean D Young [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.4]    b. Abt 1907 d. deceased b. Abt 1907 d. deceased
- 11  Jeanette Young [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.5]    b. 9 Aug 1909 d. 23 Jun 1990 b. 9 Aug 1909 d. 23 Jun 1990
 
- 11  Orrin E Young [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.3]   
 
- 10  Laurent Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.1.2]    b. 10 Nov 1876 b. 10 Nov 1876
- 10  Agnès A Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.1.3]    b. 8 Aug 1878 b. 8 Aug 1878- +  William H Cheeney  b. Abt 1883  
 
- +  William H Cheeney  b. Abt 1883  
- 10  Emma Louise Phaneuf, (A5) [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4]    b. 19 Jan 1881 d. 1 Jul 1963 b. 19 Jan 1881 d. 1 Jul 1963 Louis Patrie, (A4)  b. 24 Sep 1878 d. 29 Jan 1929 Louis Patrie, (A4)  b. 24 Sep 1878 d. 29 Jan 1929
 - 11  Louis Patrie, Jr. [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.1]    b. Sep 1903 d. 18 Jun 1904 b. Sep 1903 d. 18 Jun 1904
- 11  Lawrence George Patrie, (C2) [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.2]    b. 29 Aug 1904 d. 18 Sep 1987 b. 29 Aug 1904 d. 18 Sep 1987 Exzina C Cook, (C3)  b. 27 Nov 1909 d. 9 Jun 1941 Exzina C Cook, (C3)  b. 27 Nov 1909 d. 9 Jun 1941
 - 12  Lawrence Raymond Patrie [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.2.1]    b. 15 Nov 1928 d. 1 Feb 1929 b. 15 Nov 1928 d. 1 Feb 1929
- 12  Janet Emma Patrie, (C1) [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.2.2]    b. 28 Aug 1930 d. 31 Dec 2020
[ =>] b. 28 Aug 1930 d. 31 Dec 2020
[ =>]
- 12  Joyce Evelyn Patrie [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.2.3]    [ =>] [ =>]
- 12  James George Patrie [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.2.4]    [ =>] [ =>]
 
- 12  Lawrence Raymond Patrie [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.2.1]   
- +  Anne Nunziata White  b. 25 Mar 1919 d. 25 Dec 2004
 
- 11  Walton H Patrie, Sr. [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.3]    b. 1 Sep 1907 d. 25 Jul 1983 b. 1 Sep 1907 d. 25 Jul 1983 Jeannette M Babbie, (B1)  b. 6 Jun 1913 d. 30 Jan 1955 Jeannette M Babbie, (B1)  b. 6 Jun 1913 d. 30 Jan 1955
 - 12  Walton H Patrie, Jr. [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.3.1]    b. 6 Sep 1935 d. 23 Jul 2020
[ =>] b. 6 Sep 1935 d. 23 Jul 2020
[ =>]
- 12  Clarence Patrie [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.3.2]    b. 17 May 1937 d. 22 Dec 2021
[ =>] b. 17 May 1937 d. 22 Dec 2021
[ =>]
- 12  Richard A Patrie [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.3.3]    [ =>] [ =>]
 
- 12  Walton H Patrie, Jr. [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.3.1]   
- +  Naomi V King  b. 9 Jun 1909 d. 24 Dec 1998
 
- 11  Clarence Patrie [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.4]    b. Abt 1909 d. Abt 1910 b. Abt 1909 d. Abt 1910
- 11  Stanley Albert Patrie, (A2) [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.5]    b. 5 Feb 1912 d. 24 Nov 1995 b. 5 Feb 1912 d. 24 Nov 1995 Jean Margaret Johnston, (A3)  b. 19 Jun 1915 d. 27 Jan 2008 Jean Margaret Johnston, (A3)  b. 19 Jun 1915 d. 27 Jan 2008
 - 12  Stanley Albert Patrie, Jr. [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.5.1]    [ =>] [ =>]
- 12  Robert David Patrie, (A1) [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.5.2]    [ =>] [ =>]
- 12  Carol Judith Patrie [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.5.3]    [ =>] [ =>]
 
- 12  Stanley Albert Patrie, Jr. [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.5.1]   
 
- 11  Leonard Arthur Patrie [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.6]    b. 27 Sep 1921 d. 22 Mar 1994 b. 27 Sep 1921 d. 22 Mar 1994 Bernadette May "Bernie" Bordeau, (E1)  b. 31 Jul 1927 d. 25 Nov 2006 Bernadette May "Bernie" Bordeau, (E1)  b. 31 Jul 1927 d. 25 Nov 2006
 - 12  Leonard Louis Patrie [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.6.1]    [ =>] [ =>]
- 12  Philip J Patrie [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.6.2]    [ =>] [ =>]
- 12  Joseph Lamarque Patrie [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.6.3]    b. 29 Jan 1964 d. 24 Mar 2016 b. 29 Jan 1964 d. 24 Mar 2016
 
- 12  Leonard Louis Patrie [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.6.1]   
 
- 11  Sylvia Loretta Patrie [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.7]    b. 27 Sep 1921 d. Mar 1996 b. 27 Sep 1921 d. Mar 1996 Edward Albert Badger (Baillargeon), (D1)  b. 7 Jan 1920 d. 25 Nov 1992 Edward Albert Badger (Baillargeon), (D1)  b. 7 Jan 1920 d. 25 Nov 1992
 - 12  Albert L Badger [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.7.1]    b. 14 May 1942 d. 26 Sep 2004 b. 14 May 1942 d. 26 Sep 2004
- 12  Ronald Badger [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.7.2]     
- 12  Gail Marie Badger [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.7.3]    b. 2 Nov 1950 d. 29 Apr 2018
[ =>] b. 2 Nov 1950 d. 29 Apr 2018
[ =>]
- 12  James Loyal Badger [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.7.4]     
 
- 12  Albert L Badger [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.7.1]   
 
 
- 11  Louis Patrie, Jr. [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4.1]   
 
- 10  Elizabeth "Liz " Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.1.5]    b. Abt Apr 1883 b. Abt Apr 1883- +  Joseph Lefebvre  b. Abt Jun 1873  
 
- +  Joseph Lefebvre  b. Abt Jun 1873  
- 10  Henri Joseph Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.1.6]    b. 26 Mar 1885 d. 8 Feb 1949 b. 26 Mar 1885 d. 8 Feb 1949
- 10  George Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.1.7]    b. 20 Jun 1888 d. 21 Jan 1924 b. 20 Jun 1888 d. 21 Jan 1924 Eva Major  b. Abt 1888 d. 11 Jan 1979 Eva Major  b. Abt 1888 d. 11 Jan 1979
 - 11  Aletha Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.1.7.1]    b. 29 Feb 1916 d. 27 May 2002 b. 29 Feb 1916 d. 27 May 2002
 
- 11  Aletha Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.1.7.1]   
 
- 10  Adelaide Eva "Ida" Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.1.8]    b. 26 May 1890 d. Abt 1960 b. 26 May 1890 d. Abt 1960 Arthur Duquette  b. Abt 1888 Arthur Duquette  b. Abt 1888
 - 11  Rita M Duquette, (?) [1.2.1.1.1.1.1.2.1.8.1]    b. 28 Jul 1914 d. 5 Jul 1995 b. 28 Jul 1914 d. 5 Jul 1995
- 11  Clifford Duquette [1.2.1.1.1.1.1.2.1.8.2]    b. 24 Apr 1919 d. 6 Aug 2000 b. 24 Apr 1919 d. 6 Aug 2000
 
- 11  Rita M Duquette, (?) [1.2.1.1.1.1.1.2.1.8.1]   
 
- 10  David Alfred Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.1.9]    b. 19 Mar 1892 d. 17 Dec 1971 b. 19 Mar 1892 d. 17 Dec 1971 Mabel Major  b. 16 Jul 1894 d. 26 Aug 1961 Mabel Major  b. 16 Jul 1894 d. 26 Aug 1961
 - 11  Donald Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.1.9.1]    b. 16 Mar 1916 d. 27 Dec 1974 b. 16 Mar 1916 d. 27 Dec 1974
 
- 11  Donald Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.1.9.1]   
 
- 10  Norbert Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.1.10]    b. 16 Jun 1894 d. Abt 29 Sep 1894 b. 16 Jun 1894 d. Abt 29 Sep 1894
 
- 10  Marie J Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1]   
 
- 9  Emilie Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.2]    b. 4 Sep 1856 b. 4 Sep 1856
- 9  Laurent Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.3]    b. 16 Aug 1858 b. 16 Aug 1858
- 9  Marie Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.4]    b. Abt 1863 b. Abt 1863
- 9  Antoine Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.5]    b. Abt 1865 b. Abt 1865 Melinda "Minnie" Linton  b. Abt 1867 Melinda "Minnie" Linton  b. Abt 1867
 - 10  Albert Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.5.1]    b. 29 Aug 1884 b. 29 Aug 1884
- 10  Ida J Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.5.2]    b. Abt 1888 b. Abt 1888
- 10  Cora M Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.5.3]    b. Abt 1889 b. Abt 1889
- 10  Charles H Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.5.4]    b. Abt 1891 b. Abt 1891
 
- 10  Albert Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.5.1]   
 
- 9  Josephine Phaneuf [1.2.1.1.1.1.1.2.6]    b. Abt 1867 b. Abt 1867
 
- 9  Joseph Phaneuf, (A10) [1.2.1.1.1.1.1.2.1]   
 
 
- 8  Pierre Berthiaume [1.2.1.1.1.1.1.1]   
 
 
- 7  Marie Émilie Dufour dit Latour, (#671527) [1.2.1.1.1.1.1]   
 
 
- 6  Marquerite Angélique Laporte dit St-Georges, (#86147) [1.2.1.1.1.1]   
- +  Jean Louis Robillard, (#218973)  b. 21 Aug 1759 d. 12 Aug 1813
 
 
- 5  Marie Angélique Morin, (#124785) [1.2.1.1.1]   
 
 
- 4  Marie Madeleine Perrault, (#86357) [1.2.1.1]   
- +  Marie Anne Lescarbeau, (#46227)  b. 28 May 1701 d. Abt 6 Aug 1752
 
 
- 3  Pierre Perrault, (#62508) [1.2.1]   
 
- 2  Marie Raclos, Fille du Roi)(#4129) [1.3]    b. Abt 2 Feb 1655 d. Bef 26 Jan 1697 b. Abt 2 Feb 1655 d. Bef 26 Jan 1697- +  René Baudoin, (From France)(#3827)  b. Abt 1646 d. Abt 28 Mar 1735
 
- +  René Baudoin, (From France)(#3827)  b. Abt 1646 d. Abt 28 Mar 1735
 
- 2  Françoise Raclos, (Fille du Roi)(#24482) [1.1]   
 
